10.01.2015 Views

boletin oficial nº 157 - Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba ...

boletin oficial nº 157 - Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba ...

boletin oficial nº 157 - Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

40<br />

BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 20 <strong>de</strong> setiembre <strong>de</strong> 2012<br />

Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-<br />

Tesorero, cuatro Vocales Titu<strong>la</strong>res y tres Vocales<br />

Suplentes; Comisión Revisadores <strong>de</strong> Cuentas:<br />

Tres Miembros Titu<strong>la</strong>res y un Miembro<br />

Suplente. Todos por un año. 7° Reforma Integral<br />

<strong>de</strong> los Estatutos Sociales. 8° Designación <strong>de</strong> dos<br />

socios para firmar el Acta. El Secretario.<br />

5 días - 23860 - 27/9/2012 - $ 380<br />

SOCIEDADES<br />

COMERCIALES<br />

PIMBA S.A.<br />

EDICTO AMPLIATORIO DEL AVISO Nº<br />

6398 DE FECHA<br />

prece<strong>de</strong>ntemente, el nuevo texto <strong>de</strong>l artículo 4 <strong>de</strong>l<br />

Estatuto <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad, el que quedará redactado<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> siguiente manera: “Artículo 4: El capital<br />

social es <strong>de</strong> Pesos Ochenta y ocho mil setecientos<br />

cuatro ($ 88.704.-) representado por OCHENTA<br />

Y OCHO MIL SETECIENTAS CUATRO<br />

ACCIONES (88.704), <strong>de</strong> peso uno ($ 1.-), valor<br />

nominal cada una, ordinarias, nominativas no<br />

endosables, <strong>de</strong> c<strong>la</strong>se “A” con <strong>de</strong>recho a 5 votos<br />

por acción. El capital pue<strong>de</strong> ser aumentado por<br />

<strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Asamblea Ordinaria hasta el<br />

quíntuplo <strong>de</strong> su monto conforme al art. 188 <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

Ley 19550.<br />

3 días - 24035 – 21/9/2012 - $ 540.-<br />

PUNTA SERRANA S.A.<br />

Director Suplente: Luis Enrique Russo, D.N.I.<br />

12.250.685, nacido el 16/06/1956, divorciado,<br />

argentino, contador público, con domicilio en Lote<br />

58 Mz. 36 Country Jockey Club, ciudad <strong>de</strong><br />

Córdoba; ambos por el término <strong>de</strong> tres ejercicios,<br />

quienes aceptaron formalmente los cargos y<br />

manifiestaron con carácter <strong>de</strong> <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración jurada<br />

no encontrarse comprendidos en <strong>la</strong>s prohibiciones<br />

e incompatibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l art. 264 <strong>de</strong> <strong>la</strong> ley 19.550,<br />

fijando ambos domicilio especial en calle 27 <strong>de</strong><br />

Abril 424 Piso 10, ciudad <strong>de</strong> Córdoba.<br />

N° 24114 - $ 100.-<br />

GENSUR S.A.<br />

Elección <strong>de</strong> Autorida<strong>de</strong>s<br />

Asamblea General Ordinaria Nº 18 <strong>de</strong>l 21/12/2011<br />

se ratifica <strong>la</strong> elección y se elige nuevo director<br />

titu<strong>la</strong>r por renuncia, quedando el Directorio<br />

integrado como sigue: Presi<strong>de</strong>nte: Laurent<br />

Maurice Cadil<strong>la</strong>t (Pasaporte Francés N°<br />

11CH68724), Vicepresi<strong>de</strong>nte: Maricel Edith<br />

Cáceres (DNI Nº 21.393.956), Director Titu<strong>la</strong>r:<br />

Antony A<strong>la</strong>in Deniau (Pasaporte Francés<br />

06AR85032) y Director Suplente: Diego Martín<br />

Sabat (DNI Nº 22.560.901).-<br />

N° 24238 - $ 56.-<br />

TINTINA AGROPECUARIA S.A.<br />

Elección <strong>de</strong> Autorida<strong>de</strong>s<br />

Cambio <strong>de</strong> se<strong>de</strong> social<br />

Por medio <strong>de</strong>l presente se ratifica y amplia el<br />

Aviso N° 6398 <strong>de</strong> fecha 03/04/2012, ac<strong>la</strong>rando<br />

que <strong>la</strong>s asambleas <strong>de</strong> fechas 30/10/2009 y 21/11/<br />

2011, son <strong>de</strong> carácter ordinarias (ASAMBLEAS<br />

GENERALES ORDINARIAS). En lo <strong>de</strong>más se<br />

ratifica <strong>la</strong> mencionada publicación.<br />

N° 24111 - $ 40.-<br />

LAS FRESIAS S.A.<br />

REDUCCION DE CAPITAL<br />

Las Fresias S.A., con se<strong>de</strong> social en Moctezuma<br />

850 – Bº Lomas Oeste <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Vil<strong>la</strong> Allen<strong>de</strong><br />

– Pcia. <strong>de</strong> Córdoba, inscripta en el Registro Público<br />

<strong>de</strong> Comercio – protocolo <strong>de</strong> Contrato y<br />

Disoluciones bajo <strong>la</strong> Matrícu<strong>la</strong> Nº 1480-A,<br />

conforme a <strong>la</strong> Asamblea General Extraordinaria<br />

Unánime Nº 18 <strong>de</strong> fecha 14 <strong>de</strong> Octubre <strong>de</strong> 2011,<br />

se resolvió por unanimidad disponer <strong>la</strong> reducción<br />

<strong>de</strong>l capital social <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad LAS FRESIAS<br />

S.A. fijado en <strong>la</strong> suma <strong>de</strong> Pesos Ciento noventa y<br />

un mil doscientos noventa ($ 191.290.-) al total<br />

<strong>de</strong> Pesos Ochenta y ocho mil setecientos cuatro<br />

($ 88.704.-), quedando reducido el patrimonio<br />

neto fijado en <strong>la</strong> suma <strong>de</strong> Pesos Cuatrocientos<br />

cincuenta y un mil ciento cuarenta y tres con 90/<br />

00 ($ 451.143,90) al total <strong>de</strong> Pesos Doscientos<br />

nueve mil doscientos tres con 06/00 ($<br />

209.203,06) mediante <strong>la</strong> disminución en su<br />

importe <strong>de</strong> <strong>la</strong> suma <strong>de</strong> Pesos Doscientos cuarenta<br />

y un mil novecientos cuarenta con 84/00<br />

($241.940,84) b) Proce<strong>de</strong>r al rescate y cance<strong>la</strong>ción<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> 102.586 acciones <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ridad<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> sucesión <strong>de</strong> Luis Felipe Ferraro. c) Como<br />

contraprestación y pago por el rescate <strong>de</strong> acciones<br />

dispuesto, adjudicar a <strong>la</strong> sucesión <strong>de</strong> Luis Felipe<br />

Ferraro los siguientes bienes inmuebles, a saber:<br />

1) Departamento calle Buenos Aires 445 – 1º P. –<br />

“B” – CORDOBA, 2) Departamento Torre<br />

Milénica ubicado en calle Rodriguez <strong>de</strong>l Busto –<br />

Torre II – 2º P. – “E” – CORDOBA, 3)<br />

Departamento ubicado en Torre Elysee, calle<br />

Parana esq. San Lorenzo – Torre II – 3º P. – “A”<br />

– CORDOBA, 4) Departamento ubicado en calle<br />

Isabel La Católica 1135 – 2º P. – “A” –<br />

CORDOBA. d) Se <strong>de</strong>ja constancia que <strong>la</strong> valuación<br />

<strong>de</strong> los inmuebles adjudicados, ascien<strong>de</strong> en total a<br />

<strong>la</strong> suma <strong>de</strong> Pesos Doscientos cuarenta y un mil<br />

novecientos cuarenta con 84/00 ($ 241.940,84),<br />

que es el importe patrimonial que le correspon<strong>de</strong>n<br />

a <strong>la</strong>s acciones rescatadas conforme <strong>la</strong><br />

documentación contable oportunamente<br />

confeccionada por <strong>la</strong> sociedad, dándose por<br />

satisfecho el rescate accionario resuelto,<br />

<strong>de</strong>biéndose otorgar <strong>la</strong>s partes recíprocamente<br />

recibo y carta <strong>de</strong> pago al instrumentar <strong>la</strong><br />

adjudicación dispuesta. El rescate correspon<strong>de</strong> al<br />

53,63% <strong>de</strong>l capital social quedando el 15,55%<br />

restante en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> sucesión para ser adjudicado<br />

a <strong>la</strong>s co here<strong>de</strong>ras y accionistas Josefina Ferraro y<br />

Maria Gabrie<strong>la</strong> Ferraro conforme el convenio<br />

aludido. Seguidamente, se aprobó por unanimidad,<br />

conforme a <strong>la</strong> reducción <strong>de</strong>l capital social dispuesta<br />

RATIFICACION<br />

REFORMA DE ESTATUTO<br />

En <strong>la</strong> asamblea general ordinaria y extraordinaria<br />

<strong>de</strong> fecha 25/08/2012 se ratificaron por unanimidad<br />

<strong>la</strong> totalidad <strong>de</strong> los temas tratados y aprobados en<br />

<strong>la</strong> asamblea ordinaria y extraordinaria <strong>de</strong>l 26/08/<br />

2011. Asimismo se aprobó <strong>la</strong> modificación <strong>de</strong>l<br />

artículo 8º) <strong>de</strong>l Estatuto Social, el que quedó<br />

redactado <strong>de</strong> <strong>la</strong> siguiente manera: ARTICULO 8º:<br />

La administración estará a cargo <strong>de</strong> un Directorio<br />

compuesto con el número <strong>de</strong> miembros que fije <strong>la</strong><br />

Asamblea Ordinaria entre un mínimo <strong>de</strong> Uno (1)<br />

y un máximo <strong>de</strong> Cinco (5), electo/s por el término<br />

<strong>de</strong> dos (2) ejercicios. La Asamblea pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>signar<br />

mayor, menor o igual número <strong>de</strong> suplentes por el<br />

mismo término, con el fin <strong>de</strong> llenar <strong>la</strong>s vacantes<br />

que se produjeren en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> su elección. Los<br />

Directores en su primera reunión <strong>de</strong>berán <strong>de</strong>signar<br />

un Presi<strong>de</strong>nte y un Vicepresi<strong>de</strong>nte, en caso <strong>de</strong><br />

correspon<strong>de</strong>r, este último reemp<strong>la</strong>za al primero<br />

en caso <strong>de</strong> ausencia o impedimento. El Directorio<br />

funciona con <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> mayoría absoluta<br />

<strong>de</strong> sus miembros y resuelve por mayoría <strong>de</strong> votos<br />

presentes. No habrá remuneración para el<br />

Directorio, por lo que <strong>la</strong> tarea <strong>de</strong> dirección se<br />

entien<strong>de</strong> celebrada “ad honorem”; sin perjuicio<br />

<strong>de</strong> ello, estarán sujetas a reintegro, aquel<strong>la</strong>s<br />

erogaciones necesariamente realizadas en el<br />

cumplimiento <strong>de</strong> sus funciones. El Presi<strong>de</strong>nte tiene<br />

doble voto en caso <strong>de</strong> empate. Si se prescindiera<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> Sindicatura, <strong>la</strong> elección <strong>de</strong> Director/es<br />

Suplente/s es obligatoria.<br />

N° 24110 - $ 88.-<br />

PRODUCTORES<br />

AGRO-COMERCIAL S.A.<br />

ELECCION DE AUTORIDADES<br />

Por Asamblea General Ordinaria <strong>de</strong>l 27/03/2008<br />

se <strong>de</strong>signaron autorida<strong>de</strong>s: Director titu<strong>la</strong>r y<br />

Presi<strong>de</strong>nte: Facundo Javier Gara<strong>de</strong> Panetta, D.N.I.<br />

24.015.509, nacido el 22/04/1974, casado,<br />

argentino, abogado, con domicilio en calle 27 <strong>de</strong><br />

Abril 424 Piso 10 Of. A y B, ciudad <strong>de</strong> Córdoba;<br />

Director Suplente: Luis Enrique Russo, D.N.I.<br />

12.250.685, nacido el 16/06/1956, divorciado,<br />

argentino, contador público, con domicilio en Lote<br />

58 Mz. 36 Country Jockey Club, ciudad <strong>de</strong><br />

Córdoba; ambos por el término <strong>de</strong> tres ejercicios,<br />

quienes aceptaron formalmente los cargos y<br />

manifiestaron con carácter <strong>de</strong> <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración jurada<br />

no encontrarse comprendidos en <strong>la</strong>s prohibiciones<br />

e incompatibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l art. 264 <strong>de</strong> <strong>la</strong> ley 19.550,<br />

fijando ambos domicilio especial en <strong>la</strong> se<strong>de</strong> social<br />

sita en calle 27 <strong>de</strong> Abril 424 Piso 10, ciudad <strong>de</strong><br />

Córdoba, <strong>Provincia</strong> <strong>de</strong> Córdoba. Por Asamblea<br />

General Ordinaria <strong>de</strong>l 29/03/2011 se <strong>de</strong>signaron<br />

autorida<strong>de</strong>s: Director titu<strong>la</strong>r y Presi<strong>de</strong>nte:<br />

Facundo Javier Gara<strong>de</strong> Panetta, D.N.I.<br />

24.015.509, nacido el 22/04/1974, casado,<br />

argentino, abogado, con domicilio en calle 27 <strong>de</strong><br />

Abril 424 Piso 10 Of. A y B, ciudad <strong>de</strong> Córdoba;<br />

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 <strong>de</strong> fecha<br />

21/11/2011 se <strong>de</strong>signaron autorida<strong>de</strong>s, quedando<br />

el directorio conformado <strong>de</strong> <strong>la</strong> siguiente manera:<br />

Presi<strong>de</strong>nte, ANÍBAL JOSÉ MOCCHI, DNI Nº<br />

10.228.337; Director Suplente, JOSÉ MARCOS<br />

SARABIA, CI Nº 3.483.850-0.-<br />

N° 24240 - $ 40.-<br />

LIBERTAD S.A.<br />

Elección <strong>de</strong> Autorida<strong>de</strong>s<br />

Por Asamblea General Ordinaria Nº 57 <strong>de</strong>l 10/<br />

05/2011, Acta <strong>de</strong> Directorio N° 275 <strong>de</strong>l 10/05/<br />

2011 se eligieron autorida<strong>de</strong>s quedando<br />

conformado el directorio <strong>de</strong> <strong>la</strong> siguiente manera:<br />

Presi<strong>de</strong>nte: Jean Christophe Brin<strong>de</strong>au (DNI N°<br />

94.044.829), Vicepresi<strong>de</strong>nte: Maricel Edith<br />

Cáceres (DNI Nº 21.393.956), Directores<br />

Titu<strong>la</strong>res: Arnaud Daniel Charles Walter Joachim<br />

Strasser (Pasaporte Francés 07CH21148), Ulisses<br />

Kameyama (Pasaporte Brasilero CX754219),<br />

Bernard Petit (Pasaporte Francés 05TV77769),<br />

Patrick Emile A<strong>la</strong>in Careil (Pasaporte Francés<br />

03KE36666), Jean Pierre Chevallier (D.N.I.<br />

93.740.431), Antony A<strong>la</strong>in Deniau (Pasaporte<br />

Francés 06AR85032), y Fabrice Bernard Crouzet<br />

(Pasaporte Francés 06AZ59706); Director<br />

Suplente: Diego Martín Sabat (D.N.I.<br />

22.560.901). Asimismo por Asamblea General<br />

Ordinaria Nº 58 <strong>de</strong>l 21/12/2011 se ratifica <strong>la</strong><br />

elección y se elige nuevo director titu<strong>la</strong>r por<br />

renuncia, quedando el Directorio integrado como<br />

sigue: Presi<strong>de</strong>nte: Laurent Maurice Cadil<strong>la</strong>t<br />

(Pasaporte Francés N° 11CH68724),<br />

Vicepresi<strong>de</strong>nte: Maricel Edith Cáceres (DNI Nº<br />

21.393.956), Directores Titu<strong>la</strong>res: Arnaud Daniel<br />

Charles Walter Joachim Strasser (Pasaporte<br />

Francés 07CH21148), Ulisses Kameyama<br />

(Pasaporte Brasilero CX754219), Bernard Petit<br />

(Pasaporte Francés 05TV77769), Patrick Emile<br />

A<strong>la</strong>in Careil (Pasaporte Francés 03KE36666),<br />

Jean Pierre Chevallier (D.N.I. 93.740.431),<br />

Antony A<strong>la</strong>in Deniau (Pasaporte Francés<br />

06AR85032), y Fabrice Bernard Crouzet<br />

(Pasaporte Francés 06AZ59706); Director<br />

Suplente: Diego Martín Sabat (D.N.I.<br />

22.560.901).-<br />

N° 24237 - $ 96.-<br />

CEIBOTEL S.A.<br />

Elección <strong>de</strong> Autorida<strong>de</strong>s<br />

Por Asamblea General Ordinaria Nº 17 <strong>de</strong>l 10/<br />

05/2011 y Acta <strong>de</strong> Directorio Nº 78 <strong>de</strong> igual fecha,<br />

se eligieron autorida<strong>de</strong>s quedando conformado el<br />

directorio <strong>de</strong> <strong>la</strong> siguiente manera: Presi<strong>de</strong>nte: Jean-<br />

Christophe Mathieu Brin<strong>de</strong>au (DNI N°<br />

94.044.829), Vicepresi<strong>de</strong>nte: Maricel Edith<br />

Cáceres (DNI Nº 21.393.956), Director Titu<strong>la</strong>r:<br />

Antony A<strong>la</strong>in Deniau (Pasaporte Francés<br />

06AR85032) y Director Suplente Diego Martín<br />

Sabat (DNI Nº 22.560.901). Asimismo por<br />

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 <strong>de</strong> fecha<br />

30/08/2011 se <strong>de</strong>signaron autorida<strong>de</strong>s, quedando<br />

el directorio conformado <strong>de</strong> <strong>la</strong> siguiente manera:<br />

Presi<strong>de</strong>nte, LUIS ALBERTO RAMOS, DNI Nº<br />

8.358.176, Director Suplente, ANÍBAL JOSÉ<br />

MOCCHI, DNI Nº 10.228.337. Asimismo se<br />

estableció nuevo domicilio <strong>de</strong> se<strong>de</strong> social en calle<br />

Gregorio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ferrere Nº 2156, Barrio Tab<strong>la</strong>da<br />

Park, ciudad <strong>de</strong> Córdoba, <strong>Provincia</strong> <strong>de</strong> Córdoba,<br />

República Argentina.-<br />

N° 24239 - $ 40.-<br />

OSHER S.A.<br />

DESIGNACION DE AUTORIDADES<br />

Por Acta <strong>de</strong> Asamblea Ordinaria <strong>de</strong>l día 25 <strong>de</strong><br />

Enero <strong>de</strong> 2012, quedaron <strong>de</strong>signadas <strong>la</strong>s<br />

Autorida<strong>de</strong>s y distribución <strong>de</strong> cargos <strong>de</strong>l<br />

Directorio. PRESIDENTE, <strong>la</strong> señora NOELIA<br />

PAOLA HERNANDEZ, argentina, documento<br />

<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad DNI Nº 25.615.747 – CUIT 27-<br />

256<strong>157</strong>47– 6, mayor <strong>de</strong> edad, nacida el día 22 <strong>de</strong><br />

Diciembre <strong>de</strong> 1976, <strong>de</strong> 35 años <strong>de</strong> edad, casada,<br />

<strong>de</strong> profesión contadora pública, con domicilio en<br />

calle Ceferino <strong>de</strong> <strong>la</strong> Lastra 242 – Bº Lomas <strong>de</strong> San<br />

Martín – Córdoba. Como VICEPRESIDENTE,<br />

<strong>la</strong> señora NERINA JIMENA HERNANDEZ,<br />

argentina, documento <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad DNI Nº<br />

28.575.197 – CUIT 27-28575197-2, mayor <strong>de</strong><br />

edad, nacida el día 21 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 1981 , <strong>de</strong> 30<br />

años <strong>de</strong> edad, casada, <strong>de</strong> profesión empleada,<br />

con domicilio en calle Juan B Justo 3991 – Bº<br />

Alta Córdoba. Y como DIRECTOR SUPLENTE,<br />

<strong>la</strong> señora NADIA SOLEDAD HERNANDEZ,<br />

argentina, documento <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad DNI Nº<br />

29.818.659 – CUIT 23-29818659-4, mayor <strong>de</strong><br />

edad, nacida el día 3 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 1983 , <strong>de</strong> 28 años<br />

<strong>de</strong> edad, casada, <strong>de</strong> profesión empleada, con<br />

domicilio en calle Juan B Justo 3991 – Bº Alta<br />

Córdoba . Todos los integrantes establecen como<br />

domicilio especial en calle Avenida Juan B Justo<br />

Nº 3991 – Bº Alta Córdoba – Córdoba. Los<br />

directores <strong>de</strong>signados, titu<strong>la</strong>res y suplentes,<br />

aceptan el cargo por el cual fueron elegidos y<br />

MANIFESTAN con carácter <strong>de</strong> <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración jurada<br />

que se encuentran habilitados para el <strong>de</strong>sempeño<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong>s tareas que sus funcionen requieran, no<br />

existiendo incompatibilida<strong>de</strong>s ni limitación alguna<br />

para el logro <strong>de</strong> tal fin. No se encuentran<br />

comprendidos en <strong>la</strong>s prohibiciones e<br />

incompatibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los artículos 264 y 286 <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> Ley 19.550. Todos los directores duran en sus<br />

funciones TRES ejercicios.<br />

N° 24447 - $ 100.-<br />

JOSE GUMA S.A.<br />

Renuncia/Elección <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s – Aumento <strong>de</strong><br />

capital social – Reforma <strong>de</strong> Estatuto<br />

(1) Por Acta N° 18 <strong>de</strong> Asamblea General Ordinaria<br />

<strong>de</strong> fecha 12 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2007, se resolvió:<br />

(i) Aprobar <strong>la</strong>s renuncias presentadas por los

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!